Julia A. MCMULLEN

Julia A. MCMULLEN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Julia A. MCMULLEN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 16. Februar 1840 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Bestattung 11. Mai 1928 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37]
Tod 9. Mai 1928 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38] [39] [40]
Wohnen 1. Juni 1925 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1. Juni 1915 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1905 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1892 Ridgeway, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1855 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [45] [46]
Wohnen 1. Juni 1875 Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen New York, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1900 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen 1910 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1880 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1850 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1860 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen 1870 Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [55]
Heirat etwa 1860 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
etwa 1860
Lockport, Niagara, New York, USA
Terrance MORGAN

Notizen zu dieser Person

Died at 106 Dickenson Street, Roch. N.Y. Only shown in 1928 city directory MORGAN JULIA MORGAN (1840 - 9 May 1928) Newspaper: The Medina Tribune; Thurs., 10 May 1928 Died Wednesday morning at the home of her daughter, Mrs. P. A. GRIM ES of Rochester. The funeral will be held in Rochester at 9 o'clock Frid ay morning. Burial w ill be in St. Mary's Cemetery, Medina.

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 17, Erie, New York; Roll: 1029; Page: 4A; Enumeration District: 0132; FHL microfilm: 1241029
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Shelby, Orleans, New York; Roll: M593_1071; Page: 318A; Image: 639; Family History Library Film: 552570
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M432_499; Page: 236B; Image: 154
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buffalo Ward 19, Erie, New York; Roll: T624_946; Page: 14A; Enumeration District: 0188; FHL microfilm: 1374959
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 New York, State Census, 1855
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Buffalo Ward 17; : Erie; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 02; City: Buffalo Ward 23; : Erie; Page: 54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 32; Assembly District: 06; City: Buffalo Ward 20; : Erie; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
16 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 332; Image: 71; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: 912; Family History Film: 1254912; Page: 255C; Enumeration District: 151; Image: 0728
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
20 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 17, Erie, New York; Roll: 1029; Page: 4A; Enumeration District: 0132; FHL microfilm: 1241029
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Shelby, Orleans, New York; Roll: M593_1071; Page: 318A; Image: 639; Family History Library Film: 552570
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M432_499; Page: 236B; Image: 154
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buffalo Ward 19, Erie, New York; Roll: T624_946; Page: 14A; Enumeration District: 0188; FHL microfilm: 1374959
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1855
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Buffalo Ward 17; : Erie; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 02; City: Buffalo Ward 23; : Erie; Page: 54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 32; Assembly District: 06; City: Buffalo Ward 20; : Erie; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 332; Image: 71; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: 912; Family History Film: 1254912; Page: 255C; Enumeration District: 151; Image: 0728
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
41 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 32; Assembly District: 06; City: Buffalo Ward 20; : Erie; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 02; City: Buffalo Ward 23; : Erie; Page: 54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Buffalo Ward 17; : Erie; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
44 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 New York, State Census, 1855
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
46 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
47 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 17, Erie, New York; Roll: 1029; Page: 4A; Enumeration District: 0132; FHL microfilm: 1241029
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
50 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buffalo Ward 19, Erie, New York; Roll: T624_946; Page: 14A; Enumeration District: 0188; FHL microfilm: 1374959
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
51 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: 912; Family History Film: 1254912; Page: 255C; Enumeration District: 151; Image: 0728
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
52 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M432_499; Page: 236B; Image: 154
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
53 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 332; Image: 71; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
54 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Shelby, Orleans, New York; Roll: M593_1071; Page: 318A; Image: 639; Family History Library Film: 552570
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
55 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Shelby, Orleans, New York; Roll: M593_1071; Page: 318A; Image: 639; Family History Library Film: 552570
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person