Wallace Harrison SPILLER

Wallace Harrison SPILLER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Wallace Harrison SPILLER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 17. Oktober 1892 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [8] [9] [10] [11]
Tod 13. Februar 1978 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1920 Buxton, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1930 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1935 Portland, Cumberland, Maine nach diesem Ort suchen [14]
Wohnen 1. April 1940 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [15]
Heirat 9. Januar 1917 Portland, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen [16]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
9. Januar 1917
Portland, York, Maine, USA
Nellie Catherine PETERSEN

Quellenangaben

1 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Maine, Birth Records, 1715-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Richard Saggau Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-13 03:41:11.0
Einsender user's avatar Richard Saggau
E-Mail rasaggau@saggauchiropractic.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person