Catherine Isabell MONTEITH

Catherine Isabell MONTEITH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Catherine Isabell MONTEITH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 25. Juni 1910 [8] [9] [10] [11]
Tod 12. Dezember 1978 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1935 Fairport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1. Juni 1921 Brantford, Brant, Ontario, Canada nach diesem Ort suchen [14]
Wohnen 1911 Wellington, Ontario, Canada nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1. April 1940 Macedon, Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen 1942 Fairport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [17]
Heirat 28. Februar 1939 Fairport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18] [19]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. Februar 1939
Fairport, Monroe, New York, USA
Oliver Charles SHARP

Quellenangaben

1 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Macedon, Wayne, New York; Roll: T627_2801; Page: 5A; Enumeration District: 59-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
4 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-07-9087; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
5 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
6 1911 Census of Canada, Year: 1911; Census Place: 49 - Elora, Wellington South, Ontario; Page: 3; Family No: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
7 1921 Census of Canada, Reference Number: RG 31; Folder Number: 50; Census Place: Brantford (City), Brantford, Ontario; Page Number: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2013;
8 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Macedon, Wayne, New York; Roll: T627_2801; Page: 5A; Enumeration District: 59-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-07-9087; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
10 1911 Census of Canada, Year: 1911; Census Place: 49 - Elora, Wellington South, Ontario; Page: 3; Family No: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
11 1921 Census of Canada, Reference Number: RG 31; Folder Number: 50; Census Place: Brantford (City), Brantford, Ontario; Page Number: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2013;
12 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-07-9087; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
13 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Macedon, Wayne, New York; Roll: T627_2801; Page: 5A; Enumeration District: 59-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1921 Census of Canada, Reference Number: RG 31; Folder Number: 50; Census Place: Brantford (City), Brantford, Ontario; Page Number: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2013;
15 1911 Census of Canada, Year: 1911; Census Place: 49 - Elora, Wellington South, Ontario; Page: 3; Family No: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Macedon, Wayne, New York; Roll: T627_2801; Page: 5A; Enumeration District: 59-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
19 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person