Louise Margaret MAXSON

Louise Margaret MAXSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Louise Margaret MAXSON [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 28. November 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Bestattung Dezember 1991 Byron, Genesee, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Tod 26. Dezember 1991 Batavia, Genesee, New York, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1935 und 1993 Phoenix, Maricopa, Arizona, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1991 [30]
Heirat 25. Januar 1941 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
25. Januar 1941
Rochester, Monroe, New York, USA
Raymond Otto SCHICKER

Quellenangaben

1 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 International Genealogical Index(R), downloaded 28 May 2007
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
5 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 14A; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
8 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 12A; Enumeration District: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
9 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-03-8778; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
11 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
12 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
16 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 14A; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
17 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 12A; Enumeration District: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
18 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-03-8778; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
19 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 Louise M. Schicker obit, Rochester Democrat & Chronicle, Dec 28 1991
24 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-03-8778; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
25 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
26 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
28 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 12A; Enumeration District: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
29 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 14A; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
30 Louise M. Schicker obit, Rochester Democrat & Chronicle, Dec 28 1991
31 International Genealogical Index(R), downloaded 28 May 2007
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person