Frederick Jerome WADSWORTH

Frederick Jerome WADSWORTH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Frederick Jerome WADSWORTH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 18. Mai 1893 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
Bestattung 1943 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Tod 29. Mai 1943 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29]
Wohnen 1942 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1925 Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1. Oktober 1914 Chadwicks, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1900 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1939 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Heirat 7. August 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38] [39] [40] [41] [42]
Heirat 7. Oktober 1914 Utica, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [43] [44] [45]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
7. August 1920
Rochester, Monroe, New York, USA
Ellen Victoria CRONSHAW
Heirat Ehepartner Kinder
7. Oktober 1914
Utica, Oneida, New York, USA
Iva Blanche MATHEWS

Notizen zu dieser Person

Ran over by a train while delivering newspapers for the Rochester Democrat and Chronicle - closed casket.

Quellenangaben

1 Rhode Island, State Censuses, 1865-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 Wayne Grimes
3 Source
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 3A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 12B; Enumeration District: 0086; Image: 537.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-8026; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 12A; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
10 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
11 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 639
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
12 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
13 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
14 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
16 Rhode Island, State Censuses, 1865-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 Wayne Grimes
18 Source
19 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 3A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 12B; Enumeration District: 0086; Image: 537.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-8026; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 12A; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
24 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 639
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
25 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
26 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
27 Wayne Grimes
28 Source
29 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-8026; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 639
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
31 Rhode Island, State Censuses, 1865-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
33 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 12A; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 12B; Enumeration District: 0086; Image: 537.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 3A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 3A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 Wayne Grimes
39 Source
40 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
41 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
42 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
43 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
44 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
45 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person