Gertrude Louisa ENGLERT

Gertrude Louisa ENGLERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Gertrude Louisa ENGLERT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 10. April 1886 New York, USA nach diesem Ort suchen [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Tod 7. Mai 1967 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32] [33] [34] [35]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen Mai 1967 Beechwood, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [45] [46]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1944 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Departure Le Havre, Manche, Basse-Normandie, France nach diesem Ort suchen [50]
Arrival 23. August 1934 New York, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Heirat 4. August 1909 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [52] [53] [54] [55]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
4. August 1909
Rochester, Monroe, New York, USA
Sebastian Michael SCHICKER

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 12A; Enumeration District: 197; Image: 448
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5533; Line: 1; Page Number: 115
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 09; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 46
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2847; Page: 2A; Enumeration District: 65-201
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 091-20-9987; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 9B; Enumeration District: 0111; Image: 432.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 12B; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 15; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
14 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
15 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
16 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
17 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Page: 3; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
18 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 12A; Enumeration District: 197; Image: 448
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5533; Line: 1; Page Number: 115
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 09; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 46
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2847; Page: 2A; Enumeration District: 65-201
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 091-20-9987; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 9B; Enumeration District: 0111; Image: 432.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 12B; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 15; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
29 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
30 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Page: 3; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
32 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 091-20-9987; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 Rochester Directory 1930
34 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
35 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
36 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Page: 3; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
37 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
38 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 12A; Enumeration District: 197; Image: 448
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
39 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 15; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 09; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 46
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
44 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 12B; Enumeration District: 0167; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
45 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 9B; Enumeration District: 0111; Image: 432.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
46 Rochester Directory 1930
47 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2847; Page: 2A; Enumeration District: 65-201
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2847; Page: 2A; Enumeration District: 65-201
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
50 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5533; Line: 1; Page Number: 115
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
51 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5533; Line: 1; Page Number: 115
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
52 St Francis Xavier Marriages, Roll 6, Item 20, Diocese of Rochester records at Nazareth College Library, 1909, p21 #9
53 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
54 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
55 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person