Mary Jane MCMULLEN
♀ Mary Jane MCMULLEN
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Mary Jane MCMULLEN | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 5. November 1861 | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] |
Bestattung | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [34] [35] | |
Tod | 6. März 1948 | Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen | [36] [37] |
Wohnen | 1865 | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [38] [39] |
Wohnen | 1905 | Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen | [40] |
Wohnen | 1. Juni 1925 | Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen | [41] |
Wohnen | 1910 | Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen | [42] |
Wohnen | 1920 | Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen | [43] |
Wohnen | 1. Juni 1875 | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [44] |
Wohnen | 1900 | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [45] |
Wohnen | 1930 | McDonough, Chenango, New York, USA nach diesem Ort suchen | [46] |
Wohnen | 1880 | Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen | [47] |
Wohnen | 1935 | Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen | [48] |
Wohnen | 1. April 1940 | Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen | [49] |
Heirat | 6. Juli 1879 | [50] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
6. Juli 1879 |
Lorenzo Solomon GREENE |
|
Notizen zu dieser Person
1870 USA Federal Census Lawrance McMillin Newstead, Erie, NY abt 1828 New York White Male Wor ks on Farm Olive McMillin Newstead, Erie, NY abt 1840 New York White Female May J McMillin Newstead, Erie, NY abt 1862 New York White Female William H McMillin Newstead, Erie, NY abt 1863 New York White Male Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Rol l: M593_931; Page: 465; Image: 237.
Quellenangaben
1 | Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 465; Image: 237 |
2 | Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
3 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
4 | New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
5 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
6 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
7 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
8 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
9 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
10 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
11 | New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
12 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
13 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
14 | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
15 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
16 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
17 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
18 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
19 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
20 | Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 465; Image: 237 |
21 | Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
22 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
23 | New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
24 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
25 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
26 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
27 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
28 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
29 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
30 | New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
31 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
32 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
33 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
34 | Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
35 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
36 | Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
37 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
38 | New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
39 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
40 | New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
41 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
42 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
43 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
44 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
45 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
46 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
47 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
48 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
49 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
50 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
Datenbank
Titel | Family Grimes Stammbaum |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-30 07:34:24.0 |
Einsender | Michael Grimes |
oneofmanyangels@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |