Christian Otto FISCHER

Christian Otto FISCHER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Christian Otto FISCHER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 30. Januar 1873 Lustnau, OA Tübingen, Württemberg nach diesem Ort suchen [8]
Geburt 13. Januar 1873 Lustnau, OA Tübingen, Württemberg nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Tod 14. April 1947
Wohnen 1905 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen 1910 Brooklyn Ward 8, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Brooklyn, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Arrival November 1889 New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Arrival 19. Oktober 1924 New York, USA nach diesem Ort suchen [20]

Quellenangaben

1 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 2471; Volume #: Roll 2471 - Certificates: 392850-393349, 12 Apr 1924-14 Apr 1924
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 New York, U.S., Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Württemberg, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500–1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 8, Kings, New York; Roll: T624_959; Page: 7B; Enumeration District: 0149; FHL microfilm: 1374972
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 13 E.D. 13; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1924; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 23; Page Number: 175
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Kings
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Württemberg, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500–1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 2471; Volume #: Roll 2471 - Certificates: 392850-393349, 12 Apr 1924-14 Apr 1924
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York, U.S., Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Württemberg, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500–1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 8, Kings, New York; Roll: T624_959; Page: 7B; Enumeration District: 0149; FHL microfilm: 1374972
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 13 E.D. 13; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1924; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 23; Page Number: 175
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Kings
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 13 E.D. 13; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 8, Kings, New York; Roll: T624_959; Page: 7B; Enumeration District: 0149; FHL microfilm: 1374972
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Kings
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 New York, U.S., Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1924; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 23; Page Number: 175
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Lay(h), Haag und drumrum
Beschreibung Quellen: Kirchenbucheinträge der jeweiligen genannten Ortschaften; Inventuren und Teilungen (Zubringensinventur, Eventual- und Abteilung); Gebäudekataster Bodelshausen, Ortsfamilienbücher Mössingen, Bodelshausen, Talheim, Bötzingen, Göbrichen; Chronik der Familie Layh in Biberach, Göbrichen, Bodelshausen, Ulm und Crailsheim.
Hochgeladen 2022-07-10 11:52:26.0
Einsender user's avatar Irene Haag
E-Mail irene.haag@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person