Martha KATZ

Martha KATZ

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Martha KATZ [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Juli 1908 Betra, Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland nach diesem Ort suchen [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Tod 24. Februar 2004 Patterson, Putnam, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26]
Wohnen 20. März 1939 [27]
Wohnen 31. Mai 1942 [28]
Wohnen 1. Januar 1984
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen Patterson, NY nach diesem Ort suchen [30] [31]
Arrival 9. Oktober 1953 Quebec, Canada nach diesem Ort suchen [32]
Arrival New York nach diesem Ort suchen [33]
Departure Bremerhaven, Germany nach diesem Ort suchen [34]
Heirat 26. Mai 1934 Manhattan, New York City, New York, United States nach diesem Ort suchen [35] [36]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
26. Mai 1934
Manhattan, New York City, New York, United States
Max FIEBACK

Quellenangaben

1 New York City Ehelizenz-Index 1908-1972, https://www.myheritage.de/research/collection-10459/new-york-city-ehelizenz-index-1908-1972?itemId=3091362&action=showRecord; https://www.myheritage.de/research/collection-10459/new-york-city-ehelizenz-index-1908-1972?itemId=3091362&action=showReco
Angaben zur Veröffentlichung: MyHeritage
2 U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI), https://www.myheritage.de/research/collection-10002/us-sterbe-verzeichnis-der-sozialversicherung-ssdi?itemId=12324056&action=showRecord; https://www.myheritage.de/research/collection-10002/us-sterbe-verzeichnis-der-sozialversicherung-ssdi?itemId=12
Angaben zur Veröffentlichung: MyHeritage
3 U.S. Behördendaten Verzeichnis, https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=377831306&action=showRecord; https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=377831306&action=showRecord
Angaben zur Veröffentlichung: MyHeritage
4 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, Naturalization Records, 1882-1944, The National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Petitions for Naturalization from the U.S. District Court for the Southern District of New York, 1897-1944; Series: M1972; Roll: 1196
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, New York, Marriage License Indexes, 1907-2018, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 103-28-4151; Issue State: New York; Issue Date: 1952-1954
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York, Naturalization Records, 1882-1944, The National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Petitions for Naturalization from the U.S. District Court for the Southern District of New York, 1897-1944; Series: M1972; Roll: 1196
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947, Arolsen Archives, Digital Archive; Bad Arlosen, Germany; Lists of Persecutees 2.1.1.1; Series: 2.1.1.1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1960, The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Passengers Arriving at St. Albans, VT, District through Canadian Pacific and Atlantic Ports, 1895-1954; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Serv
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., World War II Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 103-28-4151; Issue State: New York; Issue Date: 1952-1954
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947, Arolsen Archives, Digital Archive; Bad Arlosen, Germany; Lists of Persecutees 2.1.1.1; Series: 2.1.1.1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1960, The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Passengers Arriving at St. Albans, VT, District through Canadian Pacific and Atlantic Ports, 1895-1954; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Serv
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 103-28-4151; Issue State: New York; Issue Date: 1952-1954
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947, Arolsen Archives, Digital Archive; Bad Arlosen, Germany; Lists of Persecutees 2.1.1.1; Series: 2.1.1.1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947, Arolsen Archives, Digital Archive; Bad Arlosen, Germany; Lists of Persecutees 2.1.1.1; Series: 2.1.1.1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1960, The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Passengers Arriving at St. Albans, VT, District through Canadian Pacific and Atlantic Ports, 1895-1954; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Serv
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1960, The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Passengers Arriving at St. Albans, VT, District through Canadian Pacific and Atlantic Ports, 1895-1954; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Serv
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 New York, New York, Marriage License Indexes, 1907-2018, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel TemmeWenzelBontePfeiffer
Beschreibung
Hochgeladen 2022-04-19 14:17:12.0
Einsender user's avatar Andrea Temme
E-Mail atemme@online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person