Ruth Maria WILMANNS

Ruth Maria WILMANNS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ruth Maria WILMANNS [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 1. Oktober 1903 Neuenheim, Baden nach diesem Ort suchen [12]
Geburt 18. Juni 1910 Heidelberg am Neckar nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Tod 9. Oktober 1995 New Haven, New Haven, Connecticut nach diesem Ort suchen [20] [21] [22]
Wohnen 1935 Switzerland nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1940 Baltimore, Baltimore City, Maryland, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") Maryland nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1957 Hamden, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1993 und 1994 New Haven, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1995 Woodbridge, New Haven, Connecticut nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen Woodbridge, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [29]
Departure 1937 Hamburg, Germany nach diesem Ort suchen [30]
Arrival 19. Februar 1937 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Heirat 23. November 1939 Lawrence, Long Island, New York nach diesem Ort suchen [32]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
23. November 1939
Lawrence, Long Island, New York
Theodore LIDZ

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
4 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2003.Ursprüngliche Daten - Connecticut Department of Health. Connecticut Death Index, 1949-2001. Hartford, CT, USA: Connecticut Department of Health.Ursprüngliche Daten: Connecticut D
6 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Merlin Data Publishing Corporation, comp. Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database List
8 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002, City: New Haven; State: Connecticut; Year(s): 1993-1994
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2005.Ursprüngliche Daten - 1993-2002 White Pages. Little Rock, AR, USA: Acxiom Corporation.Ursprüngliche Daten: 1993-2002 White Pages. Little Rock, AR, USA: Acxiom Corporation.
9 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Roll: m-t0627-01512; Page: 1A; Enumeration District: 4-143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S. City Directories (Beta)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.Original data - Original sources vary according to directory. The title of the specific directory being viewed is listed at the top of the image viewer page. Check the directory titl
11 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 19; Page Number: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
12 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2003.Ursprüngliche Daten - Connecticut Department of Health. Connecticut Death Index, 1949-2001. Hartford, CT, USA: Connecticut Department of Health.Ursprüngliche Daten: Connecticut D
17 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Merlin Data Publishing Corporation, comp. Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database List
18 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Roll: m-t0627-01512; Page: 1A; Enumeration District: 4-143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 19; Page Number: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
20 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2003.Ursprüngliche Daten - Connecticut Department of Health. Connecticut Death Index, 1949-2001. Hartford, CT, USA: Connecticut Department of Health.Ursprüngliche Daten: Connecticut D
23 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Roll: m-t0627-01512; Page: 1A; Enumeration District: 4-143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Roll: m-t0627-01512; Page: 1A; Enumeration District: 4-143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
26 U.S. City Directories (Beta)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.Original data - Original sources vary according to directory. The title of the specific directory being viewed is listed at the top of the image viewer page. Check the directory titl
27 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002, City: New Haven; State: Connecticut; Year(s): 1993-1994
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2005.Ursprüngliche Daten - 1993-2002 White Pages. Little Rock, AR, USA: Acxiom Corporation.Ursprüngliche Daten: 1993-2002 White Pages. Little Rock, AR, USA: Acxiom Corporation.
28 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2003.Ursprüngliche Daten - Connecticut Department of Health. Connecticut Death Index, 1949-2001. Hartford, CT, USA: Connecticut Department of Health.Ursprüngliche Daten: Connecticut D
29 U.S. Public Records Index, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Merlin Data Publishing Corporation, comp. Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database List
30 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 19; Page Number: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
31 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 19; Page Number: 96
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
32 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Weule-Woile-Datenbank 2022
Beschreibung
Hochgeladen 2022-02-13 20:53:23.0
Einsender user's avatar Reinhard Weule
E-Mail reinhard.weule@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person