Walther Heinrich Fedor SKUTSCH

Walther Heinrich Fedor SKUTSCH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Walther Heinrich Fedor SKUTSCH [2] [3] [4] [5] [6]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 26. Juni 1898 Jena, Thüringen nach diesem Ort suchen [7] [8] [9] [10]
Tod 24. Januar 1978 Garden City, Nassau, New York, USA nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1935 München, Oberbayern nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1940 North Hempstead, Nassau, New York, USA nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [14]
Departure 1938 Hamburg, Germany nach diesem Ort suchen [15]
Arrival 26. März 1938 New York, New York nach diesem Ort suchen [16] [17]
NaturalizationDeclaration 26. Mai 1938 New York nach diesem Ort suchen [18]
Heirat Leipzig nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Leipzig
Louise HETTNER

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 Social Security Death Index, Number: 052-12-9839; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: North Hempstead, Nassau, New York; Roll: m-t0627-02692; Page: 8B; Enumeration District: 30-266
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Index, 1917-1950 Declarations of Intention, U.S. District Court, Southern Dist. of New York, M1675; Microfilm Serial: M1675; Microfilm Roll: 77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1938; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6131; Line: 7; Page Number: 88
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
7 Social Security Death Index, Number: 052-12-9839; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: North Hempstead, Nassau, New York; Roll: m-t0627-02692; Page: 8B; Enumeration District: 30-266
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1938; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6131; Line: 7; Page Number: 88
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
11 Social Security Death Index, Number: 052-12-9839; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.Ursprüngliche Daten - Social Security Administration. Social Security Death Index, Master File. Social Security Administration.Ursprüngliche Daten: Social Security Administration.
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: North Hempstead, Nassau, New York; Roll: m-t0627-02692; Page: 8B; Enumeration District: 30-266
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: North Hempstead, Nassau, New York; Roll: m-t0627-02692; Page: 8B; Enumeration District: 30-266
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Index, 1917-1950 Declarations of Intention, U.S. District Court, Southern Dist. of New York, M1675; Microfilm Serial: M1675; Microfilm Roll: 77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1938; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6131; Line: 7; Page Number: 88
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
16 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1938; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6131; Line: 7; Page Number: 88
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
18 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Weule-Woile-Datenbank 2022
Beschreibung
Hochgeladen 2022-02-13 20:53:23.0
Einsender user's avatar Reinhard Weule
E-Mail reinhard.weule@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person