Sophia Anna MEYERS

Sophia Anna MEYERS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Sophia Anna MEYERS [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe Auglaize, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [15]
Geburt 15. Juli 1871 Minster, Auglaize, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20]
Tod 16. Januar 1939 Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21] [22]
Wohnen 1880 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1891 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1900 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1910 Ottawa, Putnam, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [26]

Notizen zu dieser Person

(1880) Louisville, Jefferson, KY (Roll 422, p.43b), (190 0) ("Annie") Louisville WD-3, Jeffersson, KY (Roll 529, p.7a), (1910) Louisville WD-3, Jefferson, OH (Roll 484, p.41b)

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Ohio, Births and Christenings Index, 1800-1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 Ohio 1910 Census Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 7; Enumeration District: 0028; FHL microfilm: 1240529
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Ohio, Births and Christenings Index, 1800-1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 Ohio 1910 Census Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Ohio, Births and Christenings Index, 1800-1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Ohio, Births and Christenings Index, 1800-1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Ohio 1910 Census Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 7; Enumeration District: 0028; FHL microfilm: 1240529
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Ohio 1910 Census Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person