John Sidney EVERIDGE

John Sidney EVERIDGE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name John Sidney EVERIDGE [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1. Oktober 1897 Letcher, Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
Bestattung 1976 Everidge Family Cemetery, Pine Top, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Tod 16. Dezember 1976 Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39]
Wohnen 1900 Rock House, Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1910 Precinct 3, Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1918 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1917–1918") Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1920 Upper Carr, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1930 Carr Fork, Carr Fork, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1935 Ivan, Spider, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1940 Magisterial District No 2, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1950 Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen vor 1951 Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1967 Hindman, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [49]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Bessie PIGMAN

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., World War II Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rock House, Letcher, Kentucky; Roll: 538; Page: 5; Enumeration District: 0076; FHL microfilm: 1240538
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Precinct 3, Letcher, Kentucky; Roll: T624_491; Page: 15A; Enumeration District: 0147; FHL microfilm: 1374504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Indiana, U.S., Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Indiana, U.S., Death Certificates, 1899-2011
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 Newspapers.com Marriage Index, 1800s-1999, Palladium-Item; Publication Date: 2/ Jun/ 1961; Publication Place: Richmond, Indiana, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/252763062/?article=840eb2fd-be99-4f55-b5bd-dc0eaab243df&focus=0.72475195,0.054774087,0.9744834,0.52898616&xid=3398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 One World Tree
18 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rock House, Letcher, Kentucky; Roll: 538; Page: 5; Enumeration District: 0076; FHL microfilm: 1240538
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Precinct 3, Letcher, Kentucky; Roll: T624_491; Page: 15A; Enumeration District: 0147; FHL microfilm: 1374504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Newspapers.com Marriage Index, 1800s-1999, Palladium-Item; Publication Date: 2/ Jun/ 1961; Publication Place: Richmond, Indiana, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/252763062/?article=840eb2fd-be99-4f55-b5bd-dc0eaab243df&focus=0.72475195,0.054774087,0.9744834,0.52898616&xid=3398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 One World Tree
27 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rock House, Letcher, Kentucky; Roll: 538; Page: 5; Enumeration District: 0076; FHL microfilm: 1240538
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Precinct 3, Letcher, Kentucky; Roll: T624_491; Page: 15A; Enumeration District: 0147; FHL microfilm: 1374504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 One World Tree
35 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 One World Tree
40 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rock House, Letcher, Kentucky; Roll: 538; Page: 5; Enumeration District: 0076; FHL microfilm: 1240538
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Precinct 3, Letcher, Kentucky; Roll: T624_491; Page: 15A; Enumeration District: 0147; FHL microfilm: 1374504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
49 Newspapers.com Marriage Index, 1800s-1999, Palladium-Item; Publication Date: 2/ Jun/ 1961; Publication Place: Richmond, Indiana, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/252763062/?article=840eb2fd-be99-4f55-b5bd-dc0eaab243df&focus=0.72475195,0.054774087,0.9744834,0.52898616&xid=3398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person