Miles Monroe PRATT

Miles Monroe PRATT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Miles Monroe PRATT [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 19. November 1869 Floyd, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23]
Bestattung 1930 Pratt Cemetery, Langley, Floyd, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24]
Tod 13. Januar 1929 Ironton, Lawrence, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [25] [26]
Wohnen 1870 Precinct 3, Prestonsburg, Floyd, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1880 Allen City, Floyd, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1910 Magisterial District 3, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1920 Jones Fork, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1929 Floyd, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Race

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Ella HUFF

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 Tennessee State Marriages, 1780-2002, Tennessee State Library and Archives; Nashville, TN, USA; Tennessee State Marriages, 1780-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Jones Fork, Knott, Kentucky; Roll: T625_577; Page: 5B; Enumeration District: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Allen, Floyd, Kentucky; Roll: 413; Page: 61B; Enumeration District: 124
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Precinct 3, Floyd, Kentucky; Roll: M593_461; Page: 536B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Magisterial District 3, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 4A; Enumeration District: 0089; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Wills, 1866-1983; Index, 1812-1997; Author: Kentucky. County Court (Floyd County); Probate Place: Floyd, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Michigan, U.S., Marriage Records, 1867-1952, Michigan Department of Community Health, Division of Vital Records and Health Statistics; Lansing, MI, USA; Michigan, Marriage Records, 1867-1952; Film: 27; Film Title: 13 Calhoun 09541-12769; Film Description: Calhoun (1942-1944)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Ohio, County Marriages, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Tennessee State Marriages, 1780-2002, Tennessee State Library and Archives; Nashville, TN, USA; Tennessee State Marriages, 1780-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Magisterial District 3, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 4A; Enumeration District: 0089; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Ohio, County Marriages, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Magisterial District 3, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 4A; Enumeration District: 0089; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Precinct 3, Floyd, Kentucky; Roll: M593_461; Page: 536B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Allen, Floyd, Kentucky; Roll: 413; Page: 61B; Enumeration District: 124
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Magisterial District 3, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 4A; Enumeration District: 0089; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Wills, 1866-1983; Index, 1812-1997; Author: Kentucky. County Court (Floyd County); Probate Place: Floyd, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person