Bernard Wilhelm TOBERGTE

Bernard Wilhelm TOBERGTE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Bernard Wilhelm TOBERGTE [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 28. April 1872 St. Johann, Osnabrück, Osnabruck, Lower Saxony, Germany nach diesem Ort suchen
Geburt 19. April 1872 Holtstraße 10, Osnabruck, Lower Saxony, Germany nach diesem Ort suchen [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
Bestattung nach 11. Februar 1961 Saint Joseph Cemetery, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [39] [40]
Tod 11. Februar 1961 Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41] [42] [43] [44]
Einbürgerung 1892 Ohio, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 23. September 1890 Speyer, Speyer, Rhineland-Palatinate, Germany nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1892 Springfield, Clark, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1900 Spring Grove Avenue 2408, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1905 Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1910 Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen 1930 Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1935 Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1938 Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1940 Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen 15. Januar 1946 Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen 1961 Kenton, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [55]
Arrival 19. Februar 1892 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [56] [57] [58] [59]
Departure vor 19. Februar 1892 Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands nach diesem Ort suchen [60]
FamilySearch ID
Heirat 1898 [61]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1898
Elizabeth STEIN

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 U.S., World War II Draft Cards Young Men, 1940-1947, The National Archives in St. Louis, Missouri; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 646
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01325; Page: 7A; Enumeration District: 59-77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Springfield, Ohio, U.S., Directories, 1890-1894
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Page: 14A; Enumeration District: 0052; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Page: 4; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1241279
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Roll: T624_1195; Page: 17A; Enumeration District: 0285; FHL microfilm: 1375208
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 Speyer, Germany, Domestic Help, 1875-1914
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Ohio, U.S., Newspapers.com™ Stories and Events Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 15/ Jan/ 1946; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100351071/?article=dac0de02-e5d2-4a1b-a262-79a72e7f75ff&xid=4634 &terms=Bernard_Tobergte
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 12 Feb 1961; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104588819/?article=6da4df55-d7e0-492d-a1ba-b580ffc9e017&focus=0.3828702,0.687916,0.49890473,0.83883715&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01325; Page: 7A; Enumeration District: 59-77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Springfield, Ohio, U.S., Directories, 1890-1894
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Roll: T624_1195; Page: 17A; Enumeration District: 0285; FHL microfilm: 1375208
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Speyer, Germany, Domestic Help, 1875-1914
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Ohio, U.S., Newspapers.com™ Stories and Events Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 15/ Jan/ 1946; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100351071/?article=dac0de02-e5d2-4a1b-a262-79a72e7f75ff&xid=4634 &terms=Bernard_Tobergte
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 12 Feb 1961; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104588819/?article=6da4df55-d7e0-492d-a1ba-b580ffc9e017&focus=0.3828702,0.687916,0.49890473,0.83883715&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01325; Page: 7A; Enumeration District: 59-77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Roll: T624_1195; Page: 17A; Enumeration District: 0285; FHL microfilm: 1375208
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Speyer, Germany, Domestic Help, 1875-1914
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 12 Feb 1961; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104588819/?article=6da4df55-d7e0-492d-a1ba-b580ffc9e017&focus=0.3828702,0.687916,0.49890473,0.83883715&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 12 Feb 1961; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104588819/?article=6da4df55-d7e0-492d-a1ba-b580ffc9e017&focus=0.3828702,0.687916,0.49890473,0.83883715&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 12 Feb 1961; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104588819/?article=6da4df55-d7e0-492d-a1ba-b580ffc9e017&focus=0.3828702,0.687916,0.49890473,0.83883715&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 Speyer, Germany, Domestic Help, 1875-1914
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 Springfield, Ohio, U.S., Directories, 1890-1894
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Page: 4; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1241279
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
48 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Roll: T624_1195; Page: 17A; Enumeration District: 0285; FHL microfilm: 1375208
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
50 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Page: 14A; Enumeration District: 0052; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
51 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01325; Page: 7A; Enumeration District: 59-77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01325; Page: 7A; Enumeration District: 59-77
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 Ohio, U.S., Newspapers.com™ Stories and Events Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 15/ Jan/ 1946; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100351071/?article=dac0de02-e5d2-4a1b-a262-79a72e7f75ff&xid=4634 &terms=Bernard_Tobergte
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
55 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
56 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Erlanger, Kenton, Kentucky; Page: 14A; Enumeration District: 0052; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
57 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
58 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Page: 4; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1241279
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
59 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Roll: T624_1195; Page: 17A; Enumeration District: 0285; FHL microfilm: 1375208
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
60 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
61 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 24, Hamilton, Ohio; Page: 4; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1241279
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person