Theodor Kasper FRANXMANN

Theodor Kasper FRANXMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Theodor Kasper FRANXMANN [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 28. November 1883 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Tod 31. Mai 1944 Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39] [40]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1928 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1942 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [49]

Quellenangaben

1 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 078
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 18A; Enumeration District: 59-48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 1A; Enumeration District: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0114; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Will Books, 1858-1924; Indexes, 1858-1939; Author: Kenton County (Kentucky). Clerk of the County Court; Probate Place: Kenton, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 078
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 18A; Enumeration District: 59-48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 1A; Enumeration District: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0114; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Will Books, 1858-1924; Indexes, 1858-1939; Author: Kenton County (Kentucky). Clerk of the County Court; Probate Place: Kenton, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 078
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 18A; Enumeration District: 59-48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 1A; Enumeration District: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0114; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Will Books, 1858-1924; Indexes, 1858-1939; Author: Kenton County (Kentucky). Clerk of the County Court; Probate Place: Kenton, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0114; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 1A; Enumeration District: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 18A; Enumeration District: 59-48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 18A; Enumeration District: 59-48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 078
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person