Johann Gerhard Heinrich RAUF
♂ Johann Gerhard Heinrich RAUF
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Johann Gerhard Heinrich RAUF | [17] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 2. Oktober 1860 | Bersenbrück, Osnabrück, Lower Saxony, Germany nach diesem Ort suchen | [18] |
Bestattung | 1938 | Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [19] |
Tod | 2. März 1938 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [20] |
Wohnen | 1900 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [21] |
Wohnen | 1910 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [22] |
Wohnen | 1920 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [23] |
Wohnen | 1925 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [24] |
Wohnen | 1930 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [25] |
Wohnen | 1938 | Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [26] |
Arrival | 1879 | [27] [28] [29] | |
Heirat | 5. Juni 1888 | Hamilton County, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [30] [31] [32] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
5. Juni 1888 Hamilton County, Ohio, USA |
Maria Louise KREKE |
|
Quellenangaben
1 | U.S., Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925; Roll #: 2719; Volume #: Roll 2719 - Certificates: 300-899, 06 Mar 1925-06 Mar 1925 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
2 | Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911, Kentucky Department of Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky; Kentucky Birth, Marriage and Death Records - Microfilm (1852-1910) Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | U.S., City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | Ohio, U.S., Births and Christenings Index, 1774-1973 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007 Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
10 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 12A; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340496 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
11 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
12 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
13 | U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Aug 1947; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100585990/?article=d696ba47-21bc-42d5-ab47-d9262d09604c&focus=0.3785985,0.8838705,0.49960107,0.9185825&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
17 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
18 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
20 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
21 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
22 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
23 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
24 | U.S., Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925; Roll #: 2719; Volume #: Roll 2719 - Certificates: 300-899, 06 Mar 1925-06 Mar 1925 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
25 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 12A; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340496 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
26 | Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
27 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
28 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
29 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
30 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
31 | 1900 United States Federal Census Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
32 | Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Kovermann 2024-03-30 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2024-03-30 18:22:21.0 |
Einsender | Andreas Kovermann |
kovermann@freenet.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |