Peter MÄRGENTHALER

Peter MÄRGENTHALER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Peter MÄRGENTHALER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 29. Juni 1873 Oftersheim, Mannheim, Baden, Germany nach diesem Ort suchen [13]
Geburt 25. Juni 1873 Oftersheim, Mannheim, Baden, Germany nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Tod 25. Oktober 1962 New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1910 Bronx Assembly District 32, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1915 New York, New York, New York, United States nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. Juni 1925 Warwick, Orange, New York, United States nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1935 Greenwood Lake, Orange, New York nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1940 Greenwood Lake, Orange, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen Greenwood Little, NY nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Arrival 1897 New York nach diesem Ort suchen [37] [38] [39] [40]
NaturalizationDeclaration 2. Juni 1902 New York, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Departure 4. Oktober 1906 Hamburg nach diesem Ort suchen [42]
Arrival Cuxhaven; Southampton; Cherbourg; New York nach diesem Ort suchen [43]
Departure Antwerp, Belgium nach diesem Ort suchen [44]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Philippina MARGENTHALER

Quellenangaben

1 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1882; Volume #: Roll 1882 - Certificates: 137100-137475, 01 Apr 1922-01 Apr 1922
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: New York; Roll: 1786805; Draft Board: 146
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 06; Assembly District: 02; City: Warwick; County: Orange; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 18; Enumeration District: 0231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 39; Assembly District: 23; City: New York; County: New York; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 7A; Enumeration District: 1450; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934, Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Microfilm No.: K_1796
Autor: Staatsarchiv Hamburg
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1897; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 673; Line: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greenwood Lake, Orange, New York; Roll: m-t0627-02712; Page: 4A; Enumeration District: 36-134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1882; Volume #: Roll 1882 - Certificates: 137100-137475, 01 Apr 1922-01 Apr 1922
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: New York; Roll: 1786805; Draft Board: 146
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 06; Assembly District: 02; City: Warwick; County: Orange; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 18; Enumeration District: 0231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 39; Assembly District: 23; City: New York; County: New York; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 7A; Enumeration District: 1450; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934, Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Microfilm No.: K_1796
Autor: Staatsarchiv Hamburg
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1897; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 673; Line: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greenwood Lake, Orange, New York; Roll: m-t0627-02712; Page: 4A; Enumeration District: 36-134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 18; Enumeration District: 0231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 7A; Enumeration District: 1450; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 39; Assembly District: 23; City: New York; County: New York; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 06; Assembly District: 02; City: Warwick; County: Orange; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greenwood Lake, Orange, New York; Roll: m-t0627-02712; Page: 4A; Enumeration District: 36-134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greenwood Lake, Orange, New York; Roll: m-t0627-02712; Page: 4A; Enumeration District: 36-134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1882; Volume #: Roll 1882 - Certificates: 137100-137475, 01 Apr 1922-01 Apr 1922
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: New York; Roll: 1786805; Draft Board: 146
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934, Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Microfilm No.: K_1796
Autor: Staatsarchiv Hamburg
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 18; Enumeration District: 0231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 7A; Enumeration District: 1450; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1897; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 673; Line: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934, Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Microfilm No.: K_1796
Autor: Staatsarchiv Hamburg
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934, Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Microfilm No.: K_1796
Autor: Staatsarchiv Hamburg
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1897; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 673; Line: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person