Jacob BAUST

Jacob BAUST

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Jacob BAUST [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 1875 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "26 Sept 1875") Kirchenbüchern, Baden, Preußen nach diesem Ort suchen [17] [18]
Geburt 19. September 1875 Oftersheim, Mannheim, Baden, Germany nach diesem Ort suchen [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
Tod USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1897 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Bronx Assembly District 32, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1. Juni 1925 New York, Bronx, New York, United States nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1930 Bronx, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 New York, Bronx, New York nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 New York, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen Bronx, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen Germany nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen Oftersheim nach diesem Ort suchen [39]
Departure 1892 [40]
Arrival 28. Juni 1892 New York, New York nach diesem Ort suchen [41]
Arrival 1893 [42]
Arrival 1894 [43]
NaturalizationOathofAllegiance 1. Juli 1898 Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Arrival 19. Oktober 1898 New York, New York nach diesem Ort suchen [45]
Arrival USA nach diesem Ort suchen [46]
Departure Antwerp, Belgium nach diesem Ort suchen [47]
Heirat 18. Februar 1900 New York City, New York, USA nach diesem Ort suchen [48] [49]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
18. Februar 1900
New York City, New York, USA
Anna AUWARTER

Quellenangaben

1 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 511; Volume #: Roll 511 - 01 Jul 1898-13 Jul 1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 9B; Enumeration District: 1441; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753945; Draft Board: 010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02469; Page: 6A; Enumeration District: 3-354
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 42; Assembly District: 01; City: New York; County: Bronx; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S., Dutch Reformed Church Records in Selected States, 1639-1989, The Archives of the Reformed Church in America; New Brunswick, New Jersey; East 68th Street Church, Marriages, 1880-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Baden, Germany Emigration Index, 1866-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1898; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 0036; Line: 29; Page Number: 166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Dutch Reformed Church Records in Selected States, 1639-1989, The Archives of the Reformed Church in America; New Brunswick, New Jersey; East 68th Street Church, Funerals, Register, Marriages, 1880-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 511; Volume #: Roll 511 - 01 Jul 1898-13 Jul 1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 9B; Enumeration District: 1441; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753945; Draft Board: 010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02469; Page: 6A; Enumeration District: 3-354
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 42; Assembly District: 01; City: New York; County: Bronx; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1898; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 0036; Line: 29; Page Number: 166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Baden, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1502-1985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 9B; Enumeration District: 1441; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 42; Assembly District: 01; City: New York; County: Bronx; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02469; Page: 6A; Enumeration District: 3-354
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02469; Page: 6A; Enumeration District: 3-354
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753945; Draft Board: 010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 511; Volume #: Roll 511 - 01 Jul 1898-13 Jul 1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 Baden, Germany Emigration Index, 1866-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1898; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 0036; Line: 29; Page Number: 166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Baden, Germany Emigration Index, 1866-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bronx Assembly District 32, New York, New York; Roll: T624_997; Page: 9B; Enumeration District: 1441; FHL microfilm: 1375010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0143
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1898; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 0036; Line: 29; Page Number: 166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1898; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 0036; Line: 29; Page Number: 166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 U.S., Dutch Reformed Church Records in Selected States, 1639-1989, The Archives of the Reformed Church in America; New Brunswick, New Jersey; East 68th Street Church, Marriages, 1880-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 U.S., Dutch Reformed Church Records in Selected States, 1639-1989, The Archives of the Reformed Church in America; New Brunswick, New Jersey; East 68th Street Church, Funerals, Register, Marriages, 1880-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person