Johann Dietrich " Dederick und Richard " MEINKE\MEINCKE

Johann Dietrich " Dederick und Richard " MEINKE\MEINCKE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Johann Dietrich " Dederick und Richard " MEINKE\MEINCKE [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 24. November 1850 Brockel, Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, Deutschland nach diesem Ort suchen [26]
Geburt 10. November 1850 Bothel, Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, Deutschland nach diesem Ort suchen [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]
Bestattung Lutheran All Faiths Cemetery, Middle Village, Queens County, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Tod 6. Februar 1935 759 Monroe Street, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [43] [44] [45]
Wohnen 1878 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1879 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1880 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [48] [49]
Wohnen 1883 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1884 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1888 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1889 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen 1895 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen 1905 77th 3d av, Brooklyn,NY nach diesem Ort suchen [55]
Wohnen 1910 1328 Fulton Street, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [56]
Wohnen 1. Juni 1915 36 Brooklyn Ave, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [57]
Wohnen 1920 69 Kingston Ave, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [58]
Wohnen 1. Juni 1925 767 Monroe Street, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [59]
Wohnen 1930 763 Monroe Street, Brooklyn, NY nach diesem Ort suchen [60]
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [61] [62]
Arrival 1869 [63]
Wohnort 1872 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
Einbürgerung 2. Mai 1877 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
kein City Directory Eintrag für 1882
Wohnort 1886 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnort 1890 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
kein City Directory Eintrag für 1891
kein City Directory Eintrag für 1892
kein City Directory Eintrag für 1894
Zeitungsbericht 6. Dezember 1897 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen
City Directory 1899 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen
Arrival 23. Oktober 1907 New York, New York nach diesem Ort suchen [64] [65]
Arrival 29. Mai 1912 New York, New York nach diesem Ort suchen [66]
City Directory 1933 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen
Sterbecertifikat 1935
Departure Bremen nach diesem Ort suchen [67] [68] [69]
Heirat 1882 New York, New York, USA (Census 1910) nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1882
New York, New York, USA (Census 1910)
Beke "Meta" SENGSTACKE

Quellenangaben

1 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - Mon, Dec 6, 1897 - Page 1, Mon, Dec 6, 1897
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
2 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 23, Kings, New York; Roll: T624_972; Page: 1B; Enumeration District: 0605; FHL microfilm: 1374985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 6; Page Number: 42
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
4 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 12; Page Number: 48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
5 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 30; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Roll: 1502; Page: 12A; Enumeration District: 0285; Image: 590.0; FHL microfilm: 2341237
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, New York, Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 17; City: New York; County: Kings; Page: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 18, Kings, New York; Roll: T625_1172; Page: 4A; Enumeration District: 1075; Image: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 17; Assembly District: 05; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 180
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1912; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1870; Line: 5; Page Number: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
15 Elbe-Weser Triangle, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1621–1879
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 868; Family History Film: 1254868; Page: 562C; Enumeration District: 033; Image: 0065
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Reports of Deaths of American Citizens Abroad, 1835-1974, The National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; ARC Title: Death Reports in State Department Decimal File, 1910 to 1962; NAI Number: 302021; Record Group Title: General Records of the Department of State, 1763 - 2002; Record Gro
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Elbe-Weser Triangle, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1621–1879
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 23, Kings, New York; Roll: T624_972; Page: 1B; Enumeration District: 0605; FHL microfilm: 1374985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 6; Page Number: 42
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
29 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 12; Page Number: 48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
30 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 30; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Roll: 1502; Page: 12A; Enumeration District: 0285; Image: 590.0; FHL microfilm: 2341237
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 New York, New York, Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 17; City: New York; County: Kings; Page: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 18, Kings, New York; Roll: T625_1172; Page: 4A; Enumeration District: 1075; Image: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 17; Assembly District: 05; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 180
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1912; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1870; Line: 5; Page Number: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
39 Elbe-Weser Triangle, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1621–1879
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 868; Family History Film: 1254868; Page: 562C; Enumeration District: 033; Image: 0065
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 Reports of Deaths of American Citizens Abroad, 1835-1974, The National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; ARC Title: Death Reports in State Department Decimal File, 1910 to 1962; NAI Number: 302021; Record Group Title: General Records of the Department of State, 1763 - 2002; Record Gro
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 New York, New York, Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 Reports of Deaths of American Citizens Abroad, 1835-1974, The National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; ARC Title: Death Reports in State Department Decimal File, 1910 to 1962; NAI Number: 302021; Record Group Title: General Records of the Department of State, 1763 - 2002; Record Gro
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 868; Family History Film: 1254868; Page: 562C; Enumeration District: 033; Image: 0065
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
50 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
51 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
55 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 30; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
56 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 23, Kings, New York; Roll: T624_972; Page: 1B; Enumeration District: 0605; FHL microfilm: 1374985
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
57 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 17; City: New York; County: Kings; Page: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
58 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 18, Kings, New York; Roll: T625_1172; Page: 4A; Enumeration District: 1075; Image: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
59 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 17; Assembly District: 05; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
60 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Roll: 1502; Page: 12A; Enumeration District: 0285; Image: 590.0; FHL microfilm: 2341237
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
61 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 180
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
62 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1912; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1870; Line: 5; Page Number: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
63 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 18, Kings, New York; Roll: T625_1172; Page: 4A; Enumeration District: 1075; Image: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
64 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 6; Page Number: 42
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
65 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 12; Page Number: 48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
66 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1912; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1870; Line: 5; Page Number: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
67 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 6; Page Number: 42
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
68 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1023; Line: 12; Page Number: 48
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
69 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1912; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1870; Line: 5; Page Number: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs

Datenbank

Titel Das Familiengeschlecht der Sengestake/Sengstake
Beschreibung


Meyerhof des Amtes Syke, Lahausen Nr. 1 (heute Lahauser Straße 42)
Pflugschatzregister 1519 / Bedeschatzregister 1521  Arendt Sengestake
Erbregister 1585 / 1589 Riguard Sengestacke 


https://de.wikipedia.org/wiki/Meierhof
Als Meierhof (MeiereiMeyerhof, von lateinisch maiores villae) wird ein Bauerngehöft oder -gebäude benannt,
in dem in seiner Geschichte einmal der Verwalter (der Meier) einer Landwirtschaft gelebt hat, 
die zu einer adligen oder geistlichen Grundherrschaft gehörte.

ca. 1350: Lahausen im Kirchspiel Kirchweyhe: Rolle 1 des Lehensregisters (Hodenberg, Hoyer Urkundenbuch, Band I)
Hof Ghereke
Ein Hof, Engelbert von Weyhe

Auszug aus der Kontributionsliste von 1659
Junkern Leuthe, Vollmeyer Eylert Sengstaken
- Lehen der Edelleute/Ritter („junkern leuthe“)
 
Die Vollmeyerhofstelle Sengstaken in Lahausen als Lehen der Edelleute/Ritter bezieht sich damit wohl auf den im Lehensregister 
ca.1350 genannte „Ein Hof, Engelbert von Weyhe“  


Auszug aus dem Familienstammbaum
VIII.                   Cononis von Weyhe * ca. 1240 +/-  
IX.                        Engelbert von Weyhe (Knappe) (1337, 1342 halben Zehnten von Ahausen, 1347)  
X.                            Conrad II  (Conradus)   von Weyhe  * 1281 + 1347 (Zehnten in Ahausen, 4 Hufen in Weyhe, 
                               1 Haus in Brinkum, 1 Haus in Lahausen)

Auszug aus dem Familienstammbaum
XII.                                 Arend II. von Weyhe + nach 1422  (Teilnehmer der Fehde von 1381 zwischen den Mandelsloh Brüdern 
                                      und der Stadt Bremen oo Pelleke von Barssen


Die Mandelsloher Fehde war ein Konflikt zwischen der niederadligen Familie von Mandelsloh mit ihren drei Brüdern Dietrich, Heineke und Statius gegen Erzstift und Stadt Bremen, der von 1380 bis 1381 geführt wurde.


unter Beschreibung 
Dietrich von Mandelsloh und seine Brüder Heineke und Statius in den Wirren des Lüneburger Erbfolgestreites und der Sate;
ein Gedenkblatt 500sten Wiederkehr ihrer bezüglichen Todesjahre, 1396, 1397, 1402
(W. von Mandelsloh, 1898)
Seite 60
darin im Jahr 1381     
Dietrich von Mandelsloh gehörte die Hälfte des Schlosses (Burg) und Herrschaft Bederkesa.
Vielleicht eine Möglichkeit wie die Sengestakes nach Bederkesa kamen. 
1568 ist Hinrich Sengestake in Bederkesa im 16 Pfennigschatz Register genannt.     https://gedbas.genealogy.net/person/show/1207564486



Die Ritter von Weyhe .... 
aus dem Text habe ich die Familie von Weyhe aus Weyhe folgendermaßen zusammengestellt:

I.  Lüder von Weyhe 
II     Gerverd (Gerberus) von Weyhe
III.      Arend von Weyhe
IV.         Gerberd (Garbaro) von Weyhe
V.             Gerlach von Weyhe.
V.             Heinrich von Weyhe
V.             Arend I. von Weyhe
VI.               Heinrich der Ältere von Weyhe 
VI.               Gerlach I. von Weyhe
VII.                 Gerlach II. von Weyhe
VII.                 Friedrich von Weyhe
VII.                 Brunifrith von Weyhe
VII.                 Ludolf I. von Weyhe  
VIII.                   Heinrich (Henricus) von Weyhe  * ca. 1240 +/- 
IX.                        Johann II. von Weyhe (miles/Ritter) (1288 Advokatus in Hagen, Unterweser, 1295 Lehensmann und Ministerialer 
                            des Erzbistums Bremen, 1298 als Zeuge gemeinsam mit Erpo von Weyhe und Conrad von Weyhe)
                            (1309 genannt) (senior + 1337) oo Svancken (1309 genannt) 
X.                            Ludolf IV. von Weyhe  (1309, 1327 genannt)
X.                            Johann III. von Weyhe   (1309, 1327 genannt)  
X  .                          Heinrich von Weyhe  (1309, 1327 genannt)     
X.                            Dietrich von Weyhe (1327,1348 genannt)
X.                            Hermann von Weyhe (1327 genannt)
X.                            Erpo II. von Weyhe  * 1295 (1309, 1327, 1348 genannt) oo Cunnegunde   
XI.                               Arnold IV. von Weyhe  
XI.                               Lüder III. von Weyhe  
XI.                               Sander von Weyhe     
XI.                               Erpo III. von Weyhe * um 1335 + nach 1371(Knappe) oo von Klencke
XII.                                 Hinrick von Weyhe
XII.                                 Gerhard von Weyhe 
XII.                                 Arend II. von Weyhe + nach 1422  (Teilnehmer der Fehde von 1381 zwischen den Mandelsloh Brüdern 
                                      und der Stadt Bremen oo Pelleke von Barssen
XIII.                                   Arnd III. (auch IIa.) von Weyhe + 1478 oo Adelheid von Klencke
XIV.                                     Arpo (Arp, Erp) V. von Weyhe (+ 1472) oo Lucke von Frese
                                             (1455 Umzug von Weyhe nach Bötersheim)
XV.                                          Arend (Arnd, Arnold) III. von Weyhe oo Catharina von Ahlden
XVI.                                            Jobst von Weyhe + 21.08.1583 oo Elisabeth von Staffhorst (ihre Eltern sind Joachim von Staffhorst und Anne von der Lith (Lieth))
XVII.                                              Anna von Weyhe * 1557   + 1609
XVII.                                              Johann Wilken von Weyhe * 1557 + 23.02.1617 (Zwillingsbruder zu Anna)
XVI.                                            Anton (Tönnis) von Weyhe  + um 1600 oo Anna Maria Frese
                                                   nach 1564 Landdrost im Amt Diepholz (Lemförde, Barenburg)
                                                   wohnt zwischen 1574 und 1581 in Barenburg
                                                   https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=amt_diepholz&ID=I62936&lang=de
XIII.  .                                Arp von Weyhe + 1472
XIII.                                   Burchard I von Weyhe lebt 1418
XIII.                                   Dietrich von Weyhe
XIII.                                   Rudolph von Weyhe
VIII.                   Erpo I. von Weyhe * um 1241
IX.                        Heinrich II. von Weyhe (lebt um 1280)   
IX.                        Erpo Ia. von Weyhe  Ritter ca. 1270 +/- (genannt 1316) + 1360   
X.                            Lüder (Ludwig) von Weyhe (genannt 1316, lebt 1331)
X.                            Sander (Alexander) von Weyhe (genannt 1316, lebt 1352) 
X.                            Arnold Ia. von Weyhe (Knappe genannt 1316, lebt zwischen 1331 und 1350)
XI.                              Hermann Ia. von Weyhe (genannt 1333, 1340)
XI.                              Erpo IIa. von Weyhe  (genannt 1333, 1340) + nach 1379 oo Grete
XII.                                Willeken von Weyhe
XII.                                Hermann von Weyhe
XII.                                Erp von Weyhe
X.                            Erpo III. von Weyhe * vor 1348 + nach 1371
XI.                              Arnd II. von Weyhe * vor 1350  + nach 1422
XII.                                Arnd IIa. von Weyhe * vor 1410  + vor 1470
XII.                                Rudolf/Roleff von Weyhe  * 1440 + ca. 1523 
XII.                                Dietrich von Weyhe  * ca. 1440 + nach 1482
XI.                              Hinrick von Weyhe + vor 1397  
XI.                              Gerhard von Weyhe + vor 1397
VIII.                   wahrscheinlich Cononis von Weyhe * ca. 1240 +/-  
IX.                        Engelbert von Weyhe (Knappe) (1337, 1342 halben Zehnten von Ahausen, 1347)  
X.                            Conrad II  (Conradus)   von Weyhe  * 1281 + 1347 (Zehnten in Ahausen, 4 Hufen in Weyhe, 
                               1 Haus in Brinkum, 1 Haus in Lahausen)
XI.                              Ludolf III   von Weyhe  * vor 1300 + nach 1337
XII.                                Heinrich III von Weyhe   
XII.                                Cono von Weyhe (1347 Geistlicher/Clerici)
XII.                                Arend von Weyhe (1347 Geistlicher/Clerici)
IX.                        Johann von Weyhe  (Ritter) (1331, 1337, 1347)
X.                            Arnold von Weyhe  (Knappe)  (1325, 1331,1335, 1337) (1360)
X.                            Henricus von Weyhe (Knappe) (1360) noch mal auf der Website ansehen **
X.                            Johannes von Weyhe (Knappe) (1360) noch mal auf der Website ansehen **
IX.                        Ludolf (wohl der II.) von Weyhe (1337)
X.                            Heinrich von Weyhe  Knappe  (1337, 1340) (1350) oo Oda (1340) **
X.                            Conrad von Weyhe  (1337, 1340) (1350)
X.                            Johann von Weyhe (1337, 1340) **

die Gevettern Heinrich von Weyhe (Knappe 1347) und Johann von Weyhe (Knappe 1347) **






Anna von Weihe (Weyhe) * 1557   + 1609
Epitaph in der St. Michaelis Kirche zu Lüneburg  
Johann Wilken von Weihe (Weyhe ) * 1557 + 23.02.1617 (Zwillingsbruder zu Anna)
Grabplatte in der St. Michaelis Kirche zu Lüneburg   
als Wappen: 
von Weihe (Weyhe) 
von Alten (Ahlden)    Geschlecht seiner Großmutter
von Staffhorst   Geschlecht seiner Mutter
von Liht (von der Lieth)   Geschlecht seiner Großmutter 



Hochgeladen 2024-01-16 11:32:51.0
Einsender user's avatar Sabine Sengstake Köhler
E-Mail sengstakekoehler@icloud.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person