Henrietta Mae PETERSON

Henrietta Mae PETERSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Henrietta Mae PETERSON [1] [2] [3] [4] [5]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt etwa 1904 Maine nach diesem Ort suchen [6] [7] [8] [9] [10]
Wohnen 1930 North Salem, Westchester, New York, USA nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1935 Cumberland, Cumberland, Maine nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1. April 1940 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1920 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [14]
Wohnen 1910 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [15]
Heirat 15. Juni 1921 Portland, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen [16]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
15. Juni 1921
Portland, York, Maine, USA
Ralph Frederick STEVENS

Quellenangaben

1 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Richard Saggau Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-13 03:41:11.0
Einsender user's avatar Richard Saggau
E-Mail rasaggau@saggauchiropractic.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person