Henrietta Mae PETERSON
♀ Henrietta Mae PETERSON
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | etwa 1904 | Maine nach diesem Ort suchen | [6] [7] [8] [9] [10] |
Wohnen | 1930 | North Salem, Westchester, New York, USA nach diesem Ort suchen | [11] |
Wohnen | 1935 | Cumberland, Cumberland, Maine nach diesem Ort suchen | [12] |
Wohnen | 1. April 1940 | Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen | [13] |
Wohnen | 1920 | Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen | [14] |
Wohnen | 1910 | Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen | [15] |
Heirat | 15. Juni 1921 | Portland, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen | [16] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
15. Juni 1921 Portland, York, Maine, USA |
Ralph Frederick STEVENS |
Quellenangaben
1 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
2 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
4 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
7 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
8 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
9 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
10 | Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
11 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: North Salem, Westchester, New York; Roll: 1664; Page: 3B; Enumeration District: 0290; FHL microfilm: 2341398 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
12 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
13 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Richard Saggau Family Tree |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-13 03:41:11.0 |
Einsender | Richard Saggau |
rasaggau@saggauchiropractic.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |