Annie Brackett SAWYER

Annie Brackett SAWYER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Annie Brackett SAWYER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 28. Juli 1872 Cumberland County, Maine, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Bestattung West Cumberland, Cumberland County, Maine, United States of America nach diesem Ort suchen [19]
Tod 13. März 1945 Cumberland County, Maine, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 Cumberland, Cumberland, Maine nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1920 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1900 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1910 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [26]
Heirat 1893 Portsmouth, Rockingham, New Hampshire nach diesem Ort suchen [27] [28] [29]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1893
Portsmouth, Rockingham, New Hampshire
Christian PETERSEN

Quellenangaben

1 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New Hampshire, Marriage Records Index, 1637-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 830; Page: 4B; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340565
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 Maine, Birth Records, 1715-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1892-1907 Vital Records; Roll Number: 45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659-1947, New England Historical Genealogical Society; New Hampshire Bureau of Vital Records, Concord, New Hampshire; New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659–1947
Autor: Ancestry,com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New Hampshire, Marriage Records Index, 1637-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 830; Page: 4B; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340565
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659-1947, New England Historical Genealogical Society; New Hampshire Bureau of Vital Records, Concord, New Hampshire; New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659–1947
Autor: Ancestry,com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1474; Page: 2A; Enumeration District: 3-21
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 830; Page: 4B; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340565
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T625_639; Page: 6B; Enumeration District: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 New Hampshire, Marriage Records Index, 1637-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659-1947, New England Historical Genealogical Society; New Hampshire Bureau of Vital Records, Concord, New Hampshire; New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659–1947
Autor: Ancestry,com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Richard Saggau Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-13 03:41:11.0
Einsender user's avatar Richard Saggau
E-Mail rasaggau@saggauchiropractic.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person