Nellie Catherine PETERSEN

Nellie Catherine PETERSEN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Nellie Catherine PETERSEN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. April 1898 Cumberland County, Maine, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Tod 4. März 1978 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1920 Buxton, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1900 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1910 Cumberland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1930 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1935 Portland, Cumberland, Maine nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1. April 1940 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [24]
Heirat 9. Januar 1917 Portland, York, Maine, USA nach diesem Ort suchen [25]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
9. Januar 1917
Portland, York, Maine, USA
Wallace Harrison SPILLER

Quellenangaben

1 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 007-12-7549; Issue State: Maine; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Maine, Birth Records, 1715-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 007-12-7549; Issue State: Maine; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 007-12-7549; Issue State: Maine; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buxton, York, Maine; Roll: T625_650; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: 590; Page: 13A; Enumeration District: 0040; FHL microfilm: 1240590
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cumberland, Cumberland, Maine; Roll: T624_538; Page: 4B; Enumeration District: 0049; FHL microfilm: 1374551
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: 831; Page: 5B; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 2340566
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Portland, Cumberland, Maine; Roll: T627_1476; Page: 6B; Enumeration District: 3-104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; 1908-1922 Vital Records; Roll Number: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Richard Saggau Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-13 03:41:11.0
Einsender user's avatar Richard Saggau
E-Mail rasaggau@saggauchiropractic.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person